2018-11-28 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Consejero: PLAZA MARTINEZ JOAQUIN |
Ceses/Dimisiones |
|
details |
2016-10-03 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Adm. Unico: SAMA NEIN SL |
Nombramientos |
|
details |
2016-10-03 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Consejero: PINTOR NAVARRO SL Consejero: GESTORA DE URBANISMO SL Consejero: SA... |
Ceses/Dimisiones |
|
details |
2016-08-08 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Consejero: PROMOTORA DE NEGOCIOS ARDIS SL Consejero: AVIVITES SL Consejero: S... |
Ceses/Dimisiones |
|
details |
2014-07-15 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Consejero: GONZALEZ IBAÑEZ CARLOS Consejero: PLAZA MARTINEZ JOAQUIN Consejero... |
Ceses/Dimisiones |
|
details |
2014-07-10 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Consejero: PLAZA MARTINEZ JOAQUIN ABEL Consejero: GONZALEZ ARAUZ TEODORO Cons... |
Nombramientos |
|
details |
2014-06-26 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
REPR.143 RRM: BALIU BRUGUERA EVA REPR.143 RRM: GRANELL PINAZO MANUEL REPR.143... |
Nombramientos |
|
details |
2014-01-31 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Consejero: URBAN CORDOBA DANIEL |
Ceses/Dimisiones |
|
details |
2013-08-14 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Modificado el art. 16º de los Estatutos, relativo a la formade retribución de... |
Modificaciones estatutarias |
|
details |
2013-03-14 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Apoderado: PLAZA MARTINEZ JOAQUIN |
Revocaciones |
|
details |
2012-10-10 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Consejero: GONZALEZ ARAUZ TEODORO Consejero: GONZALEZ IBAÑEZ BELEN Consejero:... |
Ceses/Dimisiones |
|
details |
2012-10-10 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Secretario: PASCUAL SERRANO IGNACIO Consejero: GONZALEZ IBAÑEZ CARLOS Conseje... |
Nombramientos |
|
details |
2012-02-28 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Capital: 743.184,58 Euros. Resultante Suscrito: 4.728.271,34 Euros. |
Ampliación de capital |
|
details |
2012-02-21 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Capital: 1.532.105,26 Euros. Resultante Suscrito: 3.985.086,76 Euros. |
Ampliación de capital |
|
details |
2011-02-18 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Cons.Del.Sol: ESCANDON PASCUAL ANA |
Nombramientos |
|
details |
2010-08-09 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Consejero: PINTOR NAVARRO SL Consejero: GESTORA DE URBANISMO SL Consejero: SA... |
Nombramientos |
|
details |
2010-06-29 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Con.Delegado: ESCANDON HUERTA AGUSTIN Presidente: ESCANDON HUERTA AGUSTIN |
Ceses/Dimisiones |
|
details |
2010-06-29 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Con.Delegado: ESCANDON PASCUAL MARIA Presidente: ESCANDON PASCUAL MARIA |
Nombramientos |
|
details |
2010-02-01 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Aud.C.Con.: CJC AUDITORES SLP |
Nombramientos |
|
details |