2020-06-10 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
APODERAD.SOL: JULIEN CLAUDE FRED DEHEINZELIN |
Revocaciones |
|
details |
2019-08-08 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
ADM.SOLIDAR.: PASCAL ANTOINE BOURZEIX |
Cancelaciones de oficio de nombramientos |
|
details |
2019-08-06 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 11, 16 Y 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ESTRUCTU... |
Modificaciones estatutarias |
|
details |
2019-08-06 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
REPR.143 RRM: GERARD JEAN PAUL AUTAJON ADM.UNICO: FINEGA SA |
Nombramientos |
|
details |
2019-08-06 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
ADM.SOLIDAR.: FINEGA SA REPR.143 RRM: GERARD JEAN PAUL AUTAJON |
Revocaciones |
|
details |
2019-01-23 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
AUDT.CTS.CON: GMP AUDITORES SAP |
Nombramientos |
|
details |
2019-01-11 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
APODERAD.SOL: JULIEN CLAUDE FRED DEHEINZELIN |
Nombramientos |
|
details |
2019-01-11 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
APODERADO: ERIC AUGUSTE BERNARD PLESSIS COULLIAUD |
Revocaciones |
|
details |
2017-06-21 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
APODERAD.SOL: GONZALEZ CARRETERO DANIEL GERARD |
Nombramientos |
|
details |
2016-01-27 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: LAFISPAIN SL. |
Otros conceptos |
|
details |
2016-01-22 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
{u'Sociedades beneficiarias': [u'LAFISPAIN SL']} |
Escisión parcial |
|
details |
2015-11-16 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Anuncio de escisión parcial.
De conformidad con lo dispuesto en los artículo... |
ESCISIÓN DE EMPRESAS |
|
details |
2015-01-19 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
AUDIT.CUENT.: GMP AUDITORES SA AUDT.CTS.CON: GMP AUDITORES SA |
Nombramientos |
|
details |
2015-01-12 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
ART.5: SUPRESION DE LA CLASE "B" DE ACCIONES. |
Modificaciones estatutarias |
|
details |
2014-03-24 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
ADM.SOLIDAR.: FINEGA SA REPR.143 RRM: GERARD JEAN PAUL AUTAJON |
Cancelaciones de oficio de nombramientos |
|
details |
2014-03-18 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
ADM.SOLIDAR.: FINEGA SA REPR.143 RRM: GERARD JEAN PAUL AUTAJON |
Nombramientos |
|
details |
2012-02-02 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Suscrito: 410.000,00 Euros. Desembolsado: 410.000,00 Euros. Resultante Suscri... |
Ampliación de capital |
|
details |
2012-01-19 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
AUDIT.CUENT.: GMP AUDITORES SA AUDT.CTS.CON: GMP AUDITORES SA |
Nombramientos |
|
details |
2011-10-24 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
LA INDUSTRIA EDITORIAL EN TODAS SUS RAMAS Y CUALQUIER NEGOCIO O ACTIVIDAD IND... |
Cambio de objeto social |
|
details |
2011-10-24 |
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) |
Sociedades absorbidas: LITOPLEX INDUSTRIA GRAFICA SA. |
Fusión por absorción |
|
details |